Recherche dans la collection


dans
Filtres
Type d'édition : Index
Affichage de 1 - 25 sur 99 résultats filtrés
 :
  1. 1
    25 objet(s) numérique(s)
    Bibliothèque / Gazette du Canada, 1841 à 1997
    No d'identification :
    2152
    ... Sweden and 229, Nrway..... 534, PA(SS DEB PA TC Il Es- C n cl ud ecl. Earl of Kimberley--Germctin CnsuLLteq in New Brunswick .......... 19, (1106) d ilu 
  2. 2
    12 objet(s) numérique(s)
    Bibliothèque / Gazette du Canada, 1841 à 1997
    No d'identification :
    2378
    ... Sweden & Nrway.. d , , - dd ........................... :. 911; (93 1 ) Switzerland, denunciatin of Extraditin Treaty & new prpsals ................ I 
  3. 3
    79 objet(s) numérique(s)
    Bibliothèque / Gazette du Canada, 1841 à 1997
    No d'identification :
    13274
    ... Sweden added t list of Special Arrangement Cuntries PC 3289 AT THE Government House AT Ottawa WEDNEsDAY, the 8th clay of July, 1949. PRESENT: His EXCELLENCY 
  4. 4
    118 objet(s) numérique(s)
    Bibliothèque / Gazette du Canada, 1841 à 1997
    No d'identification :
    10847
    ... Sweden..........................1773 (1809) Campbell, Harld L., Member of ... Sweden and Finland.........3209 (3245) Chappell, HA, Alternate Member of the 
  5. 5
    98 objet(s) numérique(s)
    Bibliothèque / Gazette du Canada, 1841 à 1997
    No d'identification :
    10615
    ... Sweden and Finland........................2333 (2355) Mayhcw. Hn. Rlert Wellington. Ambassadr Extrardinary and Pleniptentiary of Canada t Japan 
  6. 6
    68 objet(s) numérique(s)
    Bibliothèque / Gazette du Canada, 1841 à 1997
    No d'identification :
    8660
    ... Sweden, Denmark and Japan 619 (668) Cttn Waste, exprtatin f, not prhibited in certain cuntries.... 701 Enemy merchant ships, days of grace granted t 
  7. 7
    95 objet(s) numérique(s)
    Bibliothèque / Gazette du Canada, 1841 à 1997
    No d'identification :
    13405
    ... Sweden Chahter of the Statutes of 1951 pr claimëFin Force, September 1, 1951 p. 939 (1951) Incme Tax Convention Act, Canada. France declared in Force July 2 
  8. 8
    115 objet(s) numérique(s)
    Bibliothèque / Gazette du Canada, 1841 à 1997
    No d'identification :
    14573
    ... Sweden Incme Tax Agreement between Canada and Sweden Chapter 42 of the Statutes of 1951 prclaimed in Force, September 1, 1951 p. 939 (1951) Swine SJg Cattle 
  9. 9
    115 objet(s) numérique(s)
    Bibliothèque / Gazette du Canada, 1841 à 1997
    No d'identification :
    13355
    ... Sweden Chapter 42 of the $tatutes of 1951 pr- claimed in Force, September 1, 1951 p. 939 (1951) Incme War Tax Act Act to amend prclaimed in Force July 1 
  10. 10
    403 objet(s) numérique(s)
    Bibliothèque / Gazette du Canada, 1841 à 1997
    No d'identification :
    14758
    ... SWEDEN INCME TAX CNVENTIN 25. This Part may be cited as the Cana- da-Sweden /ncrne Tax Convention Act. 1984. 32â. (1) The Convention entered int be- tween 
  11. 11
    180 objet(s) numérique(s)
    Bibliothèque / Gazette du Canada, 1841 à 1997
    No d'identification :
    11995
    ... Sweden...........2636 (2655) Mercier, Françis, Chairman of the Board of ... Sweden and West Germany are being r are likely to be dumped is likely t cause 
  12. 12
    62 objet(s) numérique(s)
    Bibliothèque / Gazette du Canada, 1841 à 1997
    No d'identification :
    4814
    ... Swedish Cnsuls nuthnrized t receive prperty. etc., lft by 8udiMh subjects dying ... Sweden, 1)enmark and Iillud ..........812 (870) foreign Tugs for use in 
  13. 13
    134 objet(s) numérique(s)
    Bibliothèque / Gazette du Canada, 1841 à 1997
    No d'identification :
    12513
    ... Sweden (Canada) Ltd............ 1421 Prvidence Manufacturing C. Ltd............. 678 RIMC Ltd.......................... 678 Radtel International Limited 
  14. 14
    24 objet(s) numérique(s)
    Bibliothèque / Gazette du Canada, 1841 à 1997
    No d'identification :
    2714
    ... Sweden, Money ORDERS ......................:...........................».....:... 1873 (1873) The Netherlands, Money ORDERS .....:
  15. 15
    151 objet(s) numérique(s)
    Bibliothèque / Gazette du Canada, 1841 à 1997
    No d'identification :
    11719
    ... Sweden Ltd.. surrender of charter...... 1274 Edwards of Canada Ltd., number ... Sweden for the avidance of Duble Taxatin came int Force n Julv 11. 1900 
  16. 16
    148 objet(s) numérique(s)
    Bibliothèque / Gazette du Canada, 1841 à 1997
    No d'identification :
    13380
    ... Sweden Incme Tax Agreement bctReen Canada and Sweden Chapter 42 of the Statutes of 1951 prclaimed in Force, September 1, 1051 p. 939 (1951) Swine imprtatin 
  17. 17
    188 objet(s) numérique(s)
    Bibliothèque / Gazette du Canada, 1841 à 1997
    No d'identification :
    14619
    ... Sweden iapter 42 of the Statute* of 1951 pr* claimed in Force, September 1. 1951 p. 939 (1951) Incme Tax declared in Force Jnly 2, 1953 p. 590 (1053) Incme 
  18. 18
    148 objet(s) numérique(s)
    Bibliothèque / Gazette du Canada, 1841 à 1997
    No d'identification :
    14580
    ... Sweden Chapter 42 of the Statute* of IMI prclaimed in Force, September 1. IMI p. 9.19 (1951) Incme War Tax AH Act to amend prclaimed In Force July 1. 1950 n 
  19. 19
    98 objet(s) numérique(s)
    Bibliothèque / Gazette du Canada, 1841 à 1997
    No d'identification :
    5104
    ... Sweden at VICTORIA .......4 42 (4538) Inches, Senr Dn Fiske, Vic-Cnsul of ... Swedish Evangelical Lutheran Immanuel Church of Assinibia, Sask., Grant of land 
  20. 20
    44 objet(s) numérique(s)
    Bibliothèque / Gazette du Canada, 1841 à 1997
    No d'identification :
    9358
    ... (Sweden), at Montreal, Que ........................ vn Hassel, Dr. Henning Léopold Burkart Nartmut (Federal Republic of Gerrpany), at Toronto, not 
  21. 21
    165 objet(s) numérique(s)
    Bibliothèque / Gazette du Canada, 1841 à 1997
    No d'identification :
    14600
    ... Sweden Chapter 4J of the Statute* of 1951 prclaimed in Force, September 1, 1951 p. 939 (1951) Incme War Tax Art Act to amend prclaimed in Force July 1, 1950 
  22. 22
    105 objet(s) numérique(s)
    Bibliothèque / Gazette du Canada, 1841 à 1997
    No d'identification :
    10534
    ... Swedish Canadian Shipping Agency Ltd............... 3433 Swiss Corporation for ... Sweden Incme Tax Agreement Act, 1951 ........................2325 (2340) 
  23. 23
    217 objet(s) numérique(s)
    Bibliothèque / Gazette du Canada, 1841 à 1997
    No d'identification :
    14618
    ... Sweden Custm* Tariff settlers* effect*--six mnth* wnership requirement* dm* not apply p. 217 11644) I in n.lax Agreement between Canada and Sweden Chapter 
  24. 24
    176 objet(s) numérique(s)
    Bibliothèque / Gazette du Canada, 1841 à 1997
    No d'identification :
    11900
    ... Sweden, Ltd., Application to the Treasury Board ofr the sanctin of an agreement entered int by the to Companies......... 327 Canadian Imperial Bank of 
  25. 25
    45 objet(s) numérique(s)
    Bibliothèque / Gazette du Canada, 1841 à 1997
    No d'identification :
    4032
    ... Sweden, Extraditin Treaty between Great Britain and.....1031 (1078) Government NTICES. AGRICULTURE Cpyrights entered during the week ending 3rd July, 0 
Voulez-vous en trouver plus? Essayez d'autres outils de recherche :
Date de modification :