Recherche dans la collection


dans
Filtres
Date : 1979
Consultables en ligne : Oui
Affichage de 1 - 25 sur 79 résultats filtrés
 :
  1. 1
    128 objet(s) numérique(s)
    Bibliothèque / Gazette du Canada, 1841 à 1997
    No d'identification :
    12877
    ... X Plastics Limited 194 WILSON Ave. Trnt Drland, JOHN Calder 24 Mssbrk Cr ... Xu 9 juin 1979 La Gazette du Canada Partie I 3679 Debtor / Débiteur tddres 
  2. 2
    209 objet(s) numérique(s)
    Bibliothèque / Gazette du Canada, 1841 à 1997
    No d'identification :
    14493
    ... XU 1 Crnau. II Crnau» III C--..V Gratt Keae 1 Sfrar-Driad Ran* Dned laauat mat Caaaaa 1 Canee» 2 Caaaaa 1 Caaaaa 2 Caaaaa 1 C--.2 Mila fei (¦all) 1 2« 1 2 
  3. 3
    154 objet(s) numérique(s)
    Bibliothèque / Gazette du Canada, 1841 à 1997
    No d'identification :
    14485
    ... Xu 15 a/c - 56. LUU, Vlnh ur 19 a/c - - 3 2617 25/7/79 CMmmdaGazetufnll.Vl.lli.N.14 GazetteduCmmmdaPrti*II, Vl. 113,/V14 9Qtt/D«S/7»-3U SCHEDULE I--Cn 
  4. 4
    86 objet(s) numérique(s)
    Bibliothèque / Gazette du Canada, 1841 à 1997
    No d'identification :
    14494
    ... x daisa ces sient cnçus de manière a) a être délimités en entier par des cisns paques; b) que les cabinets et urinirs sient cachés aux regards lrsque la 
  5. 5
    104 objet(s) numérique(s)
    Bibliothèque / Gazette du Canada, 1841 à 1997
    No d'identification :
    14491
    ... X mrt S3.00" EXPLANATRY NTE (This nte is not part of the rder, but is intended only for information purpses.) This schedule of amendments contains 
  6. 6
    101 objet(s) numérique(s)
    Bibliothèque / Gazette du Canada, 1841 à 1997
    No d'identification :
    14488
    ... X lü) «ge par nares néliaf 2 50 (r») tvaae par ama* esearvpe* 1 Jg (»1 grasae «** luaiaepai pa- taae rltrsaai « Ig (ni sairet gieins et crtMeree pa taae 
  7. 7
    43 objet(s) numérique(s)
    Bibliothèque / Gazette du Canada, 1841 à 1997
    No d'identification :
    14931
    ... X PARLIAMENotary SECRETARIES RS Pl; 31. subsection 2(2) of the ParliameNotary s.42*52"d Supp Secretaries Act is repealed and the Following substituted 
  8. 8
    101 objet(s) numérique(s)
    Bibliothèque / Gazette du Canada, 1841 à 1997
    No d'identification :
    14481
    ... X)H11%M*. Cmmdt Cm Pin II. Vl 113. N 10. May 13.1*7» *C.ILC,CJ,l 145 a 14* Enregistrement DRS/79-385 8 mai 1979 LI nationale SUR LES TRANSPRTS Loi SUR 
  9. 9
    219 objet(s) numérique(s)
    Bibliothèque / Gazette du Canada, 1841 à 1997
    No d'identification :
    14487
    ... X"; (6) na supprting structure cmpsed f rds 15 mm in diameter. (i) a ... xu 21 ¦ Aaarlcan aaerlcalne 219. IARVIS. Staphanla 2 a/c 220. 10130«. tatty 
  10. 10
    116 objet(s) numérique(s)
    Bibliothèque / Gazette du Canada, 1841 à 1997
    No d'identification :
    12884
    ... X nie. Parc Auclair Saint-Félicien Cnsmmateur Cneumcr Cda 66 Cda 74 Cnsmmateur Cnsumer Cnsmmateur Cnsumer Le 22 juin 1979 June 22. 1979 Le 17 mai 1979 May 
  11. 11
    148 objet(s) numérique(s)
    Bibliothèque / Gazette du Canada, 1841 à 1997
    No d'identification :
    12869
    ... x in a newspaper, shall be published at least nce a week for a period of fur cnsecutive weeks; and when originating in the PROVINCE of Quebec r in the 
  12. 12
    46 objet(s) numérique(s)
    Bibliothèque / Gazette du Canada, 1841 à 1997
    No d'identification :
    14483
    ... X. par la grâce de Dieu. REINE du Ryaume-Lni. du Cinada et de ses autres ryaumes et territires. Chef du Commonwealth. Défenseur de a Fi A Ns bicn-aimes et 
  13. 13
    183 objet(s) numérique(s)
    Bibliothèque / Gazette du Canada, 1841 à 1997
    No d'identification :
    12882
    ... xu" (6 mm) à Mb* (13 mm) inclusivement, des scies circulaires à main ... (x) of the Lrds Day Act As directed by the Canadian Transport Commission 
  14. 14
    75 objet(s) numérique(s)
    Bibliothèque / Gazette du Canada, 1841 à 1997
    No d'identification :
    14495
    ... X being the area from the New Brunswick-Nova Scotia interprvtncial boundary t Cape Spencer. Saint John County; 2. NB 9 being the area from Cape Spencer 
  15. 15
    150 objet(s) numérique(s)
    Bibliothèque / Gazette du Canada, 1841 à 1997
    No d'identification :
    12879
    ... x (2) En plus de lavis devant être publié dans la Gazette du Canada cmme susdit, pareil avis dit être donné dans un des principaux jurnaux à Fort tirage 
  16. 16
    150 objet(s) numérique(s)
    Bibliothèque / Gazette du Canada, 1841 à 1997
    No d'identification :
    12881
    ... (x) a ple trailer ra cable reel trailer shall be equipped with at least tail ... x 200 mm headlamp, (iii) ONE Type I, 146 mm (5m inch) headlamp and ONE 
  17. 17
    148 objet(s) numérique(s)
    Bibliothèque / Gazette du Canada, 1841 à 1997
    No d'identification :
    12903
    ... X Ltd. is a whlly-wned subsidiary of AB Ltd., acquired by A Ltd. in 1972. X Ltd. is a Canadian Corporation as defined in paragraph 89(1 )(a) of the Act 
  18. 18
    155 objet(s) numérique(s)
    Bibliothèque / Gazette du Canada, 1841 à 1997
    No d'identification :
    12863
    ... X (Eq S) Power FRAC 75 Sctaauc Ge atin 60% Semi Gelatin N" S ( Fume Claat I ) SHEAREX 75% (Fume Claat I) Straight Gelatin 60% and 10% SUBMAGEL95% XACTEX 
  19. 19
    119 objet(s) numérique(s)
    Bibliothèque / Gazette du Canada, 1841 à 1997
    No d'identification :
    12885
    ... X. Lié* Date 1973 1 janvier 2 31 31 mat 30 juin 30 septembre 1974 15 janvier 31 31 mai Desert atfa) Reprt Remise accrdée Paiement Paiement Achat de 
  20. 20
    141 objet(s) numérique(s)
    Bibliothèque / Gazette du Canada, 1841 à 1997
    No d'identification :
    14486
    ... x 407. ausa ilpanif catte dune bite de 404 x 700 2.400 u 2401 12.000 12.001-24.000 24.001-48.000 48001-72000 72.301 108.900 I08.00I-168.000 168001 240.000 
  21. 21
    130 objet(s) numérique(s)
    Bibliothèque / Gazette du Canada, 1841 à 1997
    No d'identification :
    12855
    ... X wned 100 shares of A Company n June 18,1971 which he had acquired previusly at a Cost of $10 per share. B. n December 3, 1971 Mr. X made a gift of the 
  22. 22
    118 objet(s) numérique(s)
    Bibliothèque / Gazette du Canada, 1841 à 1997
    No d'identification :
    12900
    ... (x) of section II of the Lrds Day Act (RS. c. 171), for permission t Transport by truck, n the Lrds Day, perishable cmmdities nly, over public highways of 
  23. 23
    177 objet(s) numérique(s)
    Bibliothèque / Gazette du Canada, 1841 à 1997
    No d'identification :
    12875
    ... x Saint-Mathieu-de-Beleil Faillite Bankruptcy 23/ 3/79 Cde 67 12/ 4/79 Perras. Fafard, Gagnn, Inc. Montreal Guav, Diane Leblanc 1824, rue Gdin Saint-Hubert 
  24. 24
    158 objet(s) numérique(s)
    Bibliothèque / Gazette du Canada, 1841 à 1997
    No d'identification :
    12883
    ... X SYSTEMS of CANADA, LTD. n fait savir, cnfrmément aux dispsitins de la Loi sur les crpratins canadiennes, que la Bendix Systems of Canada, Ltd. a lintentin 
  25. 25
    158 objet(s) numérique(s)
    Bibliothèque / Gazette du Canada, 1841 à 1997
    No d'identification :
    12891
    ... x\ Alen 45 JHk St. KINGSTON Riel, Gwendlyn Maureen 19 Richard St. Mantick Cnsumer Cnsmmateur Cnsumer Cnsmmatrice May 28, 1979 Le 28 mai 1979 June 13, 1979 
Voulez-vous en trouver plus? Essayez d'autres outils de recherche :
Date de modification :