Recherche dans la collection


dans
Filtres
Date : 1920-1929
Consultables en ligne : Non
Affichage de 676 - 684 sur 684 résultats filtrés
 :
  1. 676
    Aucun objet numérique
    Archives / Bureaux et maîtres de poste
    No d'identification :
    2542
    District électoral :
    Iles - de - la - Maldeleine
    Province :
    Québec
    Source :
    Gouvernement
    Référence :
    RG3-D-3
    Location - Amherst Island - 1926-08-16
  2. 677
    Aucun objet numérique
    Archives / Bureaux et maîtres de poste
    No d'identification :
    21804
    District électoral :
    Strathcona
    Province :
    Alberta
    Source :
    Gouvernement
    Référence :
    RG3-D-3
    Closed 1925-03-31, mail to Cooking Lake Mail route - Ardrossan-Cooking Lake NE Sec. 1, Twp. 52, R. 22, W4M Sec. 18, Twp. 52, R. 21, W4M - 1908-06-01
  3. 678
    Aucun objet numérique
    Archives / Bureaux et maîtres de poste
    No d'identification :
    8812
    District électoral :
    Parry Sound
    Province :
    Ontario
    Source :
    Gouvernement
    Référence :
    RG3-D-3
    Office permanently closed on the 1967-12-15, due to the provision of Rural Mail Delivery Service via, Utterson RR#1. Watt - 1903-05-16
  4. 679
    Aucun objet numérique
    Archives / Bureaux et maîtres de poste
    No d'identification :
    26683
    District électoral :
    Halifax
    Province :
    Nouvelle-Écosse
    Source :
    Gouvernement
    Référence :
    RG3-D-3
    Distributing point - Halifax Dwelling - 1949-02-09 Location - 300 yards east - 1949-02-09 Mail route - Halifax and Jollimore Permanently closed 1964-01-31 
  5. 680
    Aucun objet numérique
    Archives / Bureaux et maîtres de poste
    No d'identification :
    8100
    District électoral :
    Lambton - Kent
    Province :
    Ontario
    Source :
    Gouvernement
    Référence :
    RG3-D-3
    District of Lambton, Ontario and subsequently in the Electoral District of Middlesex West Riding. Dwelling - 1949-12-13 Euphemia - 1852-10-06 name of 
  6. 681
    Aucun objet numérique
    Archives / Bureaux et maîtres de poste
    No d'identification :
    5580
    District électoral :
    Hastings - Frontenac
    Province :
    Ontario
    Source :
    Gouvernement
    Référence :
    RG3-D-3
    Carlow - 1882-06-01 Closed due to the establishment of the new mail service Lot 6, Con 14 Maple Leaf RR #1 and will receive their mail Group Mail Box 
  7. 682
    Aucun objet numérique
    Archives / Bureaux et maîtres de poste
    No d'identification :
    10373
    District électoral :
    Sherbrooke
    Province :
    Québec
    Source :
    Gouvernement
    Référence :
    RG3-D-3
    Drugstore Location - 108 B Belvedere Street - 1921-10-10 Location - 148 Belvedere Street - 1923-02-05 Location - 404 Papineau Street - 1954-06-12 Location 
  8. 683
    Aucun objet numérique
    Archives / Bureaux et maîtres de poste
    No d'identification :
    4979
    District électoral :
    Pontiac - Temiscamingue
    Province :
    Québec
    Source :
    Gouvernement
    Référence :
    RG3-D-3
    Location - Aldfield - 1890-07-01 PO permanently closed 1965-05-25 to coincide with the service served by Duclos RR no. 1
  9. 684
    Aucun objet numérique
    Archives / Bureaux et maîtres de poste
    No d'identification :
    3831
    District électoral :
    Stanstead
    Province :
    Québec
    Source :
    Gouvernement
    Référence :
    RG3-D-3
    Hardware store Location - 148 St. Patrick St. E. - 1950-12-09 Location - 201 Main St. East - 1963-03-05 Location - 209 St. Patrick St. E
Voulez-vous en trouver plus? Essayez d'autres outils de recherche :
Date de modification :